Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 12-JAN-26
sysdate: 12-JAN-26 09:42:52
Bergen County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
GILREATH, Bryan   #P308502   05-06-2005
CONTE 6 years 6 months  c/s  16
AKA NAME  CCMO4865-96,  
LOCATION   East Jersey State Prison
OFFENSE Ind.# 98-04-662  Criminal Attempt    Burglary - 3rd Degree, 5 years  
  Unlawful Possession of Weapons - 4th Degree, 1 year 6 months  c/c 
  Hindering Apprehension - 4th Degree, 1 year 6 months  c/s 
*** See PASSAIC County ***
GOMEZ, Dario   #P1343992   12-19-2025
WILCOX 10 years   864
LOCATION   Bergen County Jail
OFFENSE Ind.# 23-11-1111 Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 1st Degree, 10 years  
QASSIS, Ray   #P1337873   06-06-2025
WILCOX 3 years  c/c  466
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 24-03-266 Aggravated Assault - 3rd Degree, 3 years  
*** See BURLINGTON County ***
RODRIGUEZ, Juan   #P1323034   01-12-2024
RAMUNDO 5 years 8 months , 3 years 6 months  M/M  340
AKA NAME  MARCADO, Juan 
LOCATION   Northern State Prison
OFFENSE Ind.# 23-05-453 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years 8 months , 3 years 6 months  M/M 
VILLALONA, John   #P1335312  (1) 01-03-2025
KAZLAU 3 years  PV  187
AKA NAME  VILLALONA, John Patrick 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 24-10-1028-A Aggravated Assault - 3rd Degree, 3 years  
RELEASED 04-25-25, REVOKED 12-24-25, RET CUSTODY 10-10-25
VILLALONA, John   #P1335312  (2) 01-02-2026
DOYLE 1 year  c/c  84
AKA NAME  VILLALONA, John Patrick 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 25-11-1355A Contempt - 4th Degree, 1 year