Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 25-MAR-24
sysdate: 25-MAR-24 11:08:01
Gloucester County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
DANTONIO, James   #P1317632   06-26-2023
EASTLACK 4 years   4
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 19-06-443 Sexual Assault - 2nd Degree, 4 years  
JACKSON, Quamaine   #P1155422   02-23-2018
ALLEN-JACKSON 8 years , 6 years 9 months 18 days M/M PV  689
AKA NAME  FRESH,  
LOCATION   Bayside State Prison
OFFENSE Ind.# 16-08-676 Robbery - 2nd Degree, 8 years , 6 years 9 months 18 days M/M 
$137,700.00 Restitution  
Note 1: 6 years 9 months 18 days mandatory minimum placed on sentence.
Note 2:  mandatory minimum placed on Ind.# 16-08-676
RELEASED 10-22-23, REVOKED 02-28-24, RET CUSTODY 12-19-23
NICOLARY, Tyler   #P1019902   03-18-2016
BECKER, JR 8 years , 6 years 9 months 17 days M/M PV  101
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 15-08-564 Aggravated Assault - 2nd Degree, 8 years , 6 years 9 months 17 days M/M 
Ind.# 15-10-2459 Forgery - 3rd Degree, 3 years  c/c 
Ind.# 16-01-10 Aggravated Assault - 3rd Degree, 3 years  c/c 
$1,937.60 Restitution  
Note 1: 6 years 9 months 17 days mandatory minimum placed on sentence.
Note 2:  mandatory minimum placed on Ind.# 15-08-564
RELEASED 03-13-22, REVOKED 01-10-24, RET CUSTODY 10-23-23
RODRIGUEZ, Jonathan   #P1321141   10-27-2023
EASTLACK 3 years , 1 year  M/M  9
LOCATION   East Jersey State Prison
OFFENSE Ind.# 23-05-306 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 3 years , 1 year  M/M