Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 16-JUN-25
sysdate: 16-JUN-25 10:58:01
Hudson County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
BOON, Quadee   #P547916   11-19-2015
GALIS-MENEDEZ 7 years , 5 years 11 months 12 days M/M PV  125
AKA NAME  LOGAN, Quadee 
LOCATION   Essex County Jail
OFFENSE Ind.# 13-09-1693 Possession of C.D.S. - 3rd Degree, 5 years  
Ind.# 13-12-2316 Aggravated Sexual Assault - 1st Degree, 7 years , 5 years 11 months 12 days M/M c/c 
Ind.# 14-2-208 Sexual Assault - 2nd Degree, 7 years , 5 years 11 months 12 days M/M c/c 
Note 1:  mandatory minimum placed on Ind.# 13-12-2316
Note 2:  mandatory minimum placed on Ind.# 14-2-208
RELEASED 06-27-21, REVOKED 06-11-25, RET CUSTODY 11-11-24
PAROLED 10-26-20, REVOKED 06-11-25, RET CUSTODY 11-11-24
CAMPBELL, Teshawn   #P1338873   05-02-2025
PASCUAL 4 years   574
AKA NAME  CAMPBELL, Teshawn Kyle 
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 24-12-1619 Burglary - 3rd Degree,   2 cts c/c, 4 years  
*** See SOMERSET  UNION Counties ***
CARTER, Javis   #P1339396  (1) 05-20-2025
DESALVO 4 years   436
AKA NAME  CARTER, Javis M 
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 25-03-264 Burglary - 3rd Degree, 4 years  
Ind.# 24-10-1372 Burglary - 3rd Degree, 4 years  c/c 
Ind.# 24-07-946 Criminal Trespass - 4th Degree, 1 year 6 months  c/c 
CARTER, Javis   #P1339396  (2) 05-20-2025
MANTINEO 3 years  c/c  872
AKA NAME  CARTER, Javis M 
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 22-09-1103  VOP Burglary - 3rd Degree, 3 years  
Ind.# 22-08-993  VOP Burglary - 3rd Degree, 3 years  c/c 
Ind.# 22-08-1013  VOP Receiving Stolen Property - 3rd Degree, 3 years  c/c 
Ind.# 22-08-998  VOP Burglary - 3rd Degree, 3 years  c/c 
CRUZ, Anthony   #P1333358   10-03-2024
YOUNG, JR 5 years   2
AKA NAME  CRUZ, Michael 
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 23-12-1516 Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 1st Degree, 5 years  
Note  :  
GREEN, Akil   #P1332437   09-04-2024
YOUNG JR. 5 years , 2 years 6 months 20 days M/M  434
LOCATION   Mid-State Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 23-09-1131 Aggravated Assault - 2nd Degree, 3 years , 2 years 6 months 20 days M/M 
Ind.# 23-09-1150 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years , 1 year  M/M c/c 

Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 16-JUN-25
sysdate: 16-JUN-25 10:58:01
Hudson County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
JONES, Marquise   #P1109338   05-05-2017
YOUNG,JR 5 years , 4 years 2 months 29 days M/M PV  240
AKA NAME  JONES, Marquises 
LOCATION   Essex County Jail
OFFENSE Ind.# 16-03-0403 Armed Robbery - 1st Degree, 5 years , 4 years 2 months 29 days M/M 
Note  :  mandatory minimum placed on Ind.# 16-03-0403
RELEASED 01-18-23, REVOKED 06-11-25, RET CUSTODY 04-11-24
PALACIOS, Julian   #P1290918  (1) 01-15-2021
SCIANCALEPORE 11 months 29 days PV  2
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 19-07-811 EWC/Sexual Conduct Impair/Debauch Morals of Child - Non-Caretaker - 3rd Degree, 11 months 29 days 
PAROLED 09-27-22, REVOKED 06-11-25, RET CUSTODY 12-11-23
PALACIOS, Julian   #P1290918  (2) 06-06-2024
SERVIDIO 5 years  c/c  129
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 23-12-1472 Leaving Scene Of Fatal Accident, 5 years  
SALINAS, David   #P1339608  (1) 05-28-2025
LABIB 1 year   293
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Ind.# 24-10-1393 Theft By Unlawful Taking - 4th Degree, 1 year  
Ind.# 24-09-1259 Criminal Sexual Contact - 4th Degree, 1 year  c/c 
SALINAS, David   #P1339608  (2) 05-28-2025
LABIB 1 year  c/c  86
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Ind.# 24-01-014  VOP Unlawful Taking of Means of Conveyance - 4th Degree, 1 year  
Ind.# 21-11-1177  VOP Unlawful Taking of Means of Conveyance - 4th Degree, 1 year  c/c 
Ind.# 24-02-044-A  VOP Theft By Unlawful Taking - 4th Degree, 1 year  c/c 
$5,000.00 Restitution