Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 14-JUL-25
sysdate: 14-JUL-25 12:10:04
Union County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
BENJAMIN, Lamont   #P1334213   11-14-2024
NIEVES 4 years  PV  259
AKA NAME  BENJAMIN, Monty 
LOCATION   Bayside State Prison
OFFENSE Ind.# 23-04-226  VOP Theft By Unlawful Taking - 3rd Degree, 4 years  
Ind.# 24-04-101-A  VOP Possession of C.D.S. - 3rd Degree, 4 years  c/c 
Ind.# 23-05-299  VOP Theft By Unlawful Taking - 3rd Degree, 4 years  c/c 
RELEASED 03-10-25, REVOKED 05-28-25, RET CUSTODY 04-25-25
COOPER, Jaquil   #P1327338   05-31-2024
ROBERTS 5 years , 3 years 6 months  M/M  657
LOCATION   East Jersey State Prison
OFFENSE Ind.# 22-12-896 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years , 3 years 6 months  M/M 
GOCHEZ, Nestor   #P1340347   06-02-2025
GOVAN 4 years   603
AKA NAME  GOSHES, Nester 
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE  VOP Burglary - 3rd Degree, 4 years  
Ind.# 19-11-728
$1,943.00 Restitution  
PITTMAN, Javon   #P1267438   12-15-2023
DEITCH 7 years , 5 years 11 months 12 days M/M PV  935
AKA NAME  PITTMAN, Shaquan C 
LOCATION   Bayside State Prison
OFFENSE Ind.# 18-03-129 Manslaughter - 2nd Degree, 7 years , 5 years 11 months 12 days M/M 
Note 1:  
1265 days credit for time served 
RELEASED 12-22-23, REVOKED 03-19-25, RET CUSTODY 02-05-25