Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 24-NOV-25
sysdate: 24-NOV-25 10:59:27
Cumberland County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
BROUGHTON, Michael   #P1305849  (1) 05-13-2022
GANGLOFF 7 years , 3 years 6 months  M/M  198
AKA NAME  BROUGHTON, Michael Leonard 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 22-01-026 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 7 years , 3 years 6 months  M/M 
Ind.# 21-07-675 Aggravated Assault - 3rd Degree, 3 years  c/c 
Ind.# 22-01-027 Criminal Mischief - 4th Degree, 1 year 6 months  c/c 
*** See CAMDEN County ***
BROUGHTON, Michael   #P1305849  (2) 05-30-2025
CHIARELLO 3 years  c/c   
AKA NAME  BROUGHTON, Michael Leonard 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 25-03-171 Possession of C.D.S. - 3rd Degree, 3 years  
*** See CAMDEN County ***
CAMPBELL, Nikolas   #P1324356   03-04-2024
ZIEGLER 5 years , 3 years 6 months  M/M  444
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 23-03-157 Possession of Weapon for Unlawful Purpose - 2nd Degree, 5 years , 3 years 6 months  M/M 
EVANS, Johanan   #P1343471   11-14-2025
D'ARRIGO 5 years , 1 year  M/M  359
AKA NAME  EVANS, Keith 
LOCATION   Cumberland County Jail
OFFENSE Ind.# 15-10-911 Possession of Weapon for Unlawful Purpose - 2nd Degree, 5 years , 1 year  M/M 
*** See SALEM County ***
HUERTAS-VIDAL, Steven   #P1343484   11-14-2025
ARBITTIER 5 years , 1 year  M/M  596
AKA NAME  HUERTAS, Steven 
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Ind.# 24-06-459 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years , 1 year  M/M 
Ind.# 24-06-458 Contempt - 4th Degree, 11 months 34 days c/c 
LOZADA, Luis   #P1336146   01-22-2025
TODD 4 years  PV  552
AKA NAME  LUIS, Lozada A 
LOCATION   Bayside State Prison
OFFENSE  VOP Possession of C.D.S. - 3rd Degree, 4 years  
Ind.# 13-02-211
RELEASED 05-23-25, REVOKED 10-01-25, RET CUSTODY 09-04-25
PADILLA, Christian   #P1327858   06-17-2024
D'ARRIGO 10 years   120
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 18-02-167-A Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 1st Degree, 10 years  

Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 24-NOV-25
sysdate: 24-NOV-25 10:59:27
Cumberland County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
SMITH, George   #P1339901  (1) 06-04-2025
TODD 4 years   416
AKA NAME  SMITHH, George 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 23-09-703-A  VOP Aggravated Assault - 3rd Degree, 4 years  
$600.00 Restitution  
SMITH, George   #P1339901  (2) 10-20-2025
D'ARRIGO 1 year 6 months  c/c  48
AKA NAME  SMITHH, George 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 25-07-664 Obstructing an Administrator of the Law - 4th Degree, 1 year 6 months  
VILLAFANE, Israel   #P1343421   11-10-2025
TELSEY 5 years , 1 year  M/M  345
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Ind.# 25-02-101 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years , 1 year  M/M