Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 05-MAY-25
sysdate: 05-MAY-25 10:55:35
Hudson County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
ADAMEZ, Alan   #P1283423   12-10-2020
YOUNG 5 years , 4 years 3 months  M/M PV  677
AKA NAME  ADAMEZ, Allan S 
LOCATION   Mid-State Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 19-05-519 Robbery - 2nd Degree, 5 years , 4 years 3 months  M/M 
RELEASED 10-29-24, REVOKED 01-15-25, RET CUSTODY 11-27-24
JENKINS, Zion   #P1329783   08-16-2024
ABAD 3 years , 2 years 6 months 17 days M/M c/c  767
AKA NAME  JENKINS, Zion Zamore 
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 22-09-1144 Robbery - 2nd Degree, 3 years , 2 years 6 months 17 days M/M 
*** See ESSEX County ***
LOPEZ, Braulio   #P1325386   04-05-2024
PASCUAL 5 years   679
AKA NAME  LOPEZ, Bravlio 
LOCATION   Northern State Prison
OFFENSE Ind.# 22-04-508 Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 3rd Degree, 5 years  
*** See ESSEX County ***
RAMOSRAMOS, Juan   #P1326047   04-19-2024
ABAD 4 years   443
AKA NAME  RAMOSRAMOS, Juan Kilder 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 23-04-504 EWC/Sexual Conduct Impair/Debauch Morals of Child - Caretaker - 2nd Degree, 4 years  
ROMAN, Edwin   #P1320763   10-13-2023
YOUNG, JR. 10 years   2
AKA NAME  ROMAN, Edwin JR
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 22-08-961 Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 1st Degree, 10 years