Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 05-MAY-25
sysdate: 05-MAY-25 10:56:00
Union County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
DAVIS, Tyrone   #P1338689  (1) 04-23-2025
WISCHUSEN 1 year 6 months   137
AKA NAME  DAVIS, Tyrone A 
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Ind.# 25-02-058-A Unlawful Possession of Weapons - 4th Degree, 1 year 6 months  
DAVIS, Tyrone   #P1338689  (2) 04-23-2025
WISCHUSEN 3 months  c/c  138
AKA NAME  DAVIS, Tyrone A 
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Disposal and Transportation of Solid Waste - 3rd Degree, 3 months  
Ind.# 24-10-203-S
$6,612.89 Restitution  
EMILUS, Shawn   #P1319398   08-25-2023
DEITCH 4 years , 3 years 4 months 23 days M/M  441
LOCATION   Northern State Prison
OFFENSE Ind.# 22-10-816 Aggravated Assault - 2nd Degree,   2 cts c/c, 4 years , 3 years 4 months 23 days M/M 
HARVEY, Laquan   #P1338690   10-28-2024
NIEVES 5 years   649
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Ind.# 21-08-363-A  VOP Eluding Police - 2nd Degree, 5 years  
   VOP Receiving Stolen Property - 3rd Degree, 5 years  c/c 
HASAN, Basil   #P1335029   12-06-2024
CAULFIELD 3 years , 1 year  M/M  5
LOCATION   Bayside State Prison
OFFENSE Ind.# 24-03-210 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree,   2 cts c/c, 3 years , 1 year  M/M 
MOZO, David   #P1336325  (1) 01-31-2025
RODRIGUEZ JR 5 years   169
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 24-11-335-A Aggravated Assault - 3rd Degree,   2 cts c/c, 5 years  
MOZO, David   #P1336325  (2) 01-31-2025
RODRIGUEZ JR 3 years  c/c  231
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 22-11-477-A  VOP Possession of Weapon for Unlawful Purpose - 3rd Degree, 3 years  
$10,209.00 Restitution  
QAWWAM, Saeed   #P1338591   04-11-2025
CAULFIELD 3 years , 1 year  M/M  407
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Ind.# 24-04-392 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 3 years , 1 year  M/M