Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 25-MAR-24
sysdate: 25-MAR-24 11:08:30
Union County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
ALZATE, Jayden   #P1324094   02-16-2024
CAULFIELD 3 years   109
AKA NAME  POPOFF,  
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 23-12-308-A Receiving Stolen Property - 3rd Degree, 3 years  
Ind.# 23-12-307-A Eluding Police - 2nd Degree, 3 years  c/c 
  Resisting Arrest - 3rd Degree, 3 years  c/c 
*** See MONMOUTH County ***
CELI, Norberto   #P1321756   10-27-2023
CAULFIELD 3 years , 1 year  M/M  7
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 23-07-455 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 3 years , 1 year  M/M 
HUNTER-PERELLO, Darnell   #P1322145   03-01-2024
HUDSON 4 years  c/c  739
AKA NAME  HUNTER, Darnell 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 22-02-099 Eluding Police - 3rd Degree, 4 years  
  Theft By Unlawful Taking - 3rd Degree, 4 years  c/c 
Ind.# 22-02-108 Eluding Police - 3rd Degree, 4 years  c/c 
*** See MIDDLESEX County ***
REYESSEVILLA, Pedro   #P1324815   02-23-2024
CAULFIELD 5 years   449
AKA NAME  SEVILLA, Pedro J 
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 2nd Degree, 5 years  
Ind.# 23-12-304-A
ROSALES, Wilberto   #P1322786   01-05-2024
BORETZ 3 years   7
AKA NAME  ROSALES, Wilbert Edward 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 22-06-456 Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 2nd Degree, 3 years  
RUIZ, Israel   #P1314023   03-01-2024
CAULFIELD 3 years , 1 year  M/M c/c  194
AKA NAME  JUNIOR,  
LOCATION   Northern State Prison
OFFENSE Ind.# 23-02-079 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 3 years , 1 year  M/M 
*** See MIDDLESEX County ***
TISTA-ESPINOZA, Henry   #P1312365   12-09-2022
KIRSCH 3 years , 2 years 6 months 17 days M/M  253
AKA NAME  TISTA, Henry A 
LOCATION   Northern State Prison
OFFENSE Ind.# 22-06-452 Aggravated Assault - 2nd Degree, 3 years , 2 years 6 months 17 days M/M 
  Aggravated Assault - 3rd Degree, 3 years  c/c 

Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 25-MAR-24
sysdate: 25-MAR-24 11:08:30
Union County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
WAITERS, Quideem   #P1322578  (1) 12-08-2023
BORETZ 3 years   91
AKA NAME  WAITERS, Quideem Kareem 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 23-08-535 Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 3rd Degree, 3 years  
WAITERS, Quideem   #P1322578  (2) 03-07-2024
BORETZ 3 years  c/c  90
AKA NAME  WAITERS, Quideem Kareem 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Terroristic Threats - 3rd Degree, 3 years  
Ind.# 23-12-869
Ind.# 23-12-871 Contempt - 4th Degree, 1 year 6 months  c/c 
WHITE, Willie   #P1084439   12-09-2016
CAULFIELD 5 years , 4 years 2 months 29 days M/M PV  319
AKA NAME  WHITE, Hassan R 
LOCATION   Mid-State Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 15-08-566 Armed Robbery - 1st Degree, 5 years , 4 years 2 months 29 days M/M 
Note  :  mandatory minimum placed on Ind.# 15-08-566
RELEASED 04-24-20, REVOKED 11-01-23, RET CUSTODY 10-20-23
WILLIAMS, Sidney   #P1079222   10-28-2016
MEGA 7 years , 4 years 3 months  M/M PV  559
AKA NAME  WILLIAMS, Sidney H 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 15-10-678 Aggravated Assault - 2nd Degree, 5 years , 4 years 2 months 30 days M/M 
  Poss Firearm for Unlawful Purpose - 2nd Degree, 7 years , 3 years 6 months  M/M c/c 
*** See MIDDLESEX County ***
Note 1: 4 years 3 months  mandatory minimum placed on sentence.
Note 2:  mandatory minimum placed on Ind.# 15-10-678
RELEASED 11-15-20, REVOKED 03-20-24, RET CUSTODY 07-02-23